SERVICIOS COLECTIVOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Quirze, 30
Código Postal 08201
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Razón Social SERVICIOS COLECTIVOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL SA
CIF A08776429
Actividad Depósito y almacenamiento
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SERVICIOS COLECTIVOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS COLECTIVOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bombardo Navines Jose | Presidente | 30/07/2015 | 12/12/2018 |
Bombardo Navines Jose | Consejero | 30/07/2015 | 12/12/2018 |
Bombardo Navines Jose | Apoderado Solidario | 17/08/2015 | 12/12/2018 |
Garcia Planas Marcet Francesc | Consejero | 30/07/2015 | 12/12/2018 |
Garcia Planas Marcet Francesc | Apoderado Solidario | 17/08/2015 | 12/12/2018 |
Garrell Guiu Antonio Cosme | Consejero | 30/07/2015 | 12/12/2018 |
Garrell Guiu Antonio Cosme | Apoderado Solidario | 17/08/2015 | 12/12/2018 |
Grau Bedos Joan Carles | Liquidador | 12/12/2018 | 12/12/2018 |
Grau Bedos Joan Carles | Secretario | 30/07/2015 | 12/12/2018 |
Grau Bedos Joan Carles | Consejero | 30/07/2015 | 12/12/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVICIOS COLECTIVOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44957 , F 191, S 8, H B 118174, I/A 29 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 33 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44957 , F 191, S 8, H B 118174, I/A 29 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44957 , F 191, S 8, H B 118174, I/A 29 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44957 , F 191, S 8, H B 118174, I/A 29 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27425 , F 31, S 8, H B 118174, I/A 28 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 25 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27425 , F 30, S 8, H B 118174, I/A 27 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27425 , F 30, S 8, H B 118174, I/A 27 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27425 , F 30, S 8, H B 118174, I/A 27 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.13,21,25 Y 33.- CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27425 , F 29, S 8, H B 118174, I/A 26 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-08