VUELTA OMEGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 202
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VUELTA OMEGA SL
CIF B85394310
Capital Social 680000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 24/03/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VUELTA OMEGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VUELTA OMEGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aburto Uriarte Guillermo | Apoderado | 21/05/2013 | 22/12/2015 |
Aguirregomezcorta Caubet Tatiana | Vicesecret. | 20/03/2009 | 22/12/2015 |
Arroyo Mira Juan Jose | Apoderado | 21/05/2013 | 22/12/2015 |
Bros Tejedor Federico | Apoderado | 21/05/2013 | 22/12/2015 |
Cabrera Rebato Susana | Apoderado | 21/05/2013 | 22/12/2015 |
Castillo Navarro Reverter Paloma | Apoderado | 21/05/2013 | 22/12/2015 |
D`hommee Caupers Pedro Jose | Presidente | 21/05/2013 | 22/12/2015 |
D`hommee Caupers Pedro Jose | Consejero | 22/12/2015 | |
D'hommee Caupes Pedro-jose | Consejero | 19/05/2009 | 22/12/2015 |
De Castro Ribeiro Joaquin Fernando | Consejero | 09/09/2010 | 22/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VUELTA OMEGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 220, S 8, H M 458153, I/A 16 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 220, S 8, H M 458153, I/A 16 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 220, S 8, H M 458153, I/A 16 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-28
Apoderado
- Aburto Uriarte Guillermo
- Arroyo Mira Juan Jose
- Bros Tejedor Federico
- Cabrera Rebato Susana
- Castillo Navarro Reverter Paloma
- Diez Moncalvillo Angel Luis
- Dominguez Lavadores Fernando
- Durao Fernandez Alexandre Miguel
- Fernandez Pelaez Mar
- Galguera Garcia Carlos
- Gamboa Abreu Pessegueiro Alexandre
- Gistau Cosculluela Maria
- Gonzalez Suarez Patricica
- Izquierdo Esteban Delia
- Lobao Organista Da Sousa Mota Ana- Celeste
- Roncero Villaroya Antonio
- Sanz Jimenez Jose Florencio
- Simontalero Santurino Antonio
- Suarez Tramon Enrique Victor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 217, S 8, H M 458153, I/A 15 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-28
Apoderado
- Amaro Sanchez Adolfo
- Cordero Irles Francisco
- D`hommee Caupers Pedro Jose
- De Castro Ribeiro Joaquin Fernando
- Durao Fernandes Alexandre Miguel
- Gamboa Abreu Pessegueiro Alexandre
- Izquierdo Esteban Delia
- Martin-borregon Castañeda Jose Antonio
- Medina Barroso De Figueiredo Jose Edmundo
- Muñoz Terradez Carlos
- Sanchez Aparicio Luis
- Sanz Jimenez Jose Florencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 217, S 8, H M 458153, I/A 15 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 217, S 8, H M 458153, I/A 15 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 202 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 217, S 8, H M 458153, I/A 14 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 217, S 8, H M 458153, I/A 13 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 217, S 8, H M 458153, I/A 13 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-28