SURMEYCA SL
Dirección social AVDA DE LOS TRABAJADORES 28 - POLIGONO INDUSTRIAL
Municipio San Roque
Provincia Cádiz
Razón Social SURMEYCA SL
CIF B72024789
Actividad Reparación y mantenimiento naval
Fecha de Constitución 14/06/2006
Teléfono 95 609 64 52
Página Web www.surmeyca.com
Nombres Anteriores
- SURMEYCA SLL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Jeffrey Lawrence Gold
Propietario BEVELLE CAPITAL SL
Auditor Medina Lamadrid Pedro
ORGANIGRAMA DE SURMEYCA SL
VINCULACIONES DE SURMEYCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SURMEYCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sebastian Jesus Alvarez Ruiz | Apoderado | 26/10/2023 | |
BEVELLE CAPITAL SL | Socio Unico | 19/10/2023 | |
Alexander Jamet | Consejero | 01/09/2023 | |
Jeffrey Lawrence Gold | Consejero | 01/09/2023 | |
Jeffrey Lawrence Gold | Presidente | 01/09/2023 | |
Sebastian Maria Nicolussi | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/09/2023 | |
Sebastian Maria Nicolussi | Consejero | 01/09/2023 | |
Sebastian Maria Nicolussi | Secretario | 01/09/2023 | |
Gold Jeffrey Lawrence | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/08/2022 | |
Olid Manchego Daniel | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/08/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SURMEYCA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 32916, I/A 15 (02/12/2024)
CVE: BORME-A-2024-237-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 155, S 8, H CA 32916, I/A 14 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 154, S 8, H CA 32916, I/A 13 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-11
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2127 , F 32, S 8, H CA 32916, I/A 12 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-11
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2127 , F 31, S 8, H CA 32916, I/A 11 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-11
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2127 , F 31, S 8, H CA 32916, I/A 11 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-11
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2127 , F 31, S 8, H CA 32916, I/A 10 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-11
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2127 , F 30, S 8, H CA 32916, I/A 9 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-11
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2127 , F 30, S 8, H CA 32916, I/A 9 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2127 , F 30, S 8, H CA 32916, I/A 9 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-11