PRODIMED SA
Dirección social Calle Guzman El Bueno, 74
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PRODIMED SA
CIF A78665270
Capital Social 94273.2 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Teléfono 91 535 16 72
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Garcia Monzon Y Diaz De Isla Roberto
Auditor CONSULTORES SAYMA SA
ORGANIGRAMA DE PRODIMED SA
VINCULACIONES DE PRODIMED SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRODIMED SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Monzon Y Diaz De Isla Roberto | Administrador Unico | 13/10/2016 | |
Alvarez Valtville Rogelio | Representante | 16/09/2009 | |
Camps Guerrero Antonio | Vicesecret. | 16/09/2009 | |
INVERSIONES BAHIA BLANCA SA | Consejero Delegado | 16/09/2009 | |
De Mendoza Y Garcia Monzon Alejandro | Consejero | 09/09/2009 | |
Garcia Monzon Alonso Carlos | Vicepresidente | 09/09/2009 | |
Garcia Monzon Alonso Carlos | Consejero | 09/09/2009 | |
Garcia Monzon Y Diaz De Isla Roberto | Presidente | 09/09/2009 | |
INVERSIONES BAHIA BLANCA SA | Vicesecret. | 09/09/2009 | |
INVERSIONES BAHIA BLANCA SA | Consejero | 09/09/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PRODIMED SA
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29520 , F 178, S 8, H M 85599, I/A 28 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 5º, 7º, 8º, 10º, 14º, 15º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 24º, 25º, 26º, 29º y SUPRESION DEL ARTICULO 22º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29520 , F 178, S 8, H M 85599, I/A 28 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29520 , F 178, S 8, H M 85599, I/A 28 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29520 , F 178, S 8, H M 85599, I/A 28 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-28
- INSCRIPCION de la sentencia que declara la NULIDAD de los acuerdos sociales adoptados en las Juntas generales de accionistas de la sociedad de fechas 14 de abril de 2009 y 8 de julio de 2009 y CANCELACION de las inscripciones 24ª, 25ª y 26ª de la hoja de la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29520 , F 178, S 8, H M 85599, I/A 27 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28
- ALZAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DE ANOTACION PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE IMPUGNACION DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE 14-4-2009 Y 8-7- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10272 , F 225, S 8, H M 85599, I/A B (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-28
- MEDIANTE AUTO DE 22 DE DICIEMBRE DE 2010 DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 7 DE MADRID SE ORDENA LA ANOTACION PREVENTIVADE LA DEMANDA DE IMPUGNACION DE LOS ACUERDOS SOCIALES ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL DE " PRODIMED SA " DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2009 .-MEDIANTE AUTO DE 22 DE DICIEMBRE DE 2010 DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 7 DE MADRID SE ORDENA LA ANOTACION PREVENTIVADE LA DEMANDA DE IMPUGNACION DE LOS ACUERDOS SOCIALES ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL DE " PRODIMED SA " DE FECHA 8 DE JULIO DE 2009 .-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10272 , F 225, S 8, H M 85599, I/A A (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-28
Consejero Delegado
Representante
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10272 , F 224, S 8, H M 85599, I/A 26 (16/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10272 , F 224, S 8, H M 85599, I/A 26 (16/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-28