PECUNIA CARDS E.D.E. SL
Dirección social Avda de Bruselas, 35
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PECUNIA CARDS E.D.E. SL
CIF B86972346
Capital Social 969446.1 Euros
Página Web www.pecunpay.es
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario TRAMASIERRAS 2021 SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
ORGANIGRAMA DE PECUNIA CARDS E.D.E. SL
VINCULACIONES DE PECUNIA CARDS E.D.E. SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PECUNIA CARDS E.D.E. SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benavides Garcia Cristina | Apoderado | 19/12/2024 | |
Lage Lopez Rosa Maria | Apoderado Solidario | 03/12/2024 | |
Benavides Garcia Cristina | Apoderado | 13/11/2024 | |
Calvo Ramirez Maria | Apoderado | 13/11/2024 | |
De Carvalho Paulo Eyder Martins | Apoderado | 13/11/2024 | |
Godoy Maroto Antonio | Apoderado | 13/11/2024 | |
Ortiz Del Castillo Olivares Patricia | Apoderado | 13/11/2024 | |
Forteza Garau Miguel | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/10/2024 | |
Paniagua Borrell Moises | Apoderado | 13/02/2024 | |
Vazquez Gonzalez David | Apoderado | 13/02/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PECUNIA CARDS E.D.E. SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 582661, I/A 56 (19/12/2024)
CVE: BORME-A-2024-249-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 582661, I/A 55 (03/12/2024)
CVE: BORME-A-2024-238-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 582661, I/A 54 (13/11/2024)
CVE: BORME-A-2024-224-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 582661, I/A 54 (13/11/2024)
CVE: BORME-A-2024-224-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 582661, I/A 53 (03/10/2024)
CVE: BORME-A-2024-196-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 582661, I/A 53 (03/10/2024)
CVE: BORME-A-2024-196-28
- Otras modificaciones estatutarias: 1. REFUNDICION ESTATUTOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 582661, I/A 52 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-28
- INHABILITACION DE DON MANUEL FRANCISCO JAVIER GUIRARO PARGA POR EL PLAZO DE DOS AÑOS.INHABILITACION DE DON ANTONIO BERNARDO GARCIA CRUZ POR EL PLAZO DE TRES AÑOS. INHABILITACION DE DON JOSE RAMON MONREAL DOMEC POR EL PLAZO DE 3 AÑOS. TODO ELLOS PARA EJERCER CARGOS DE ADMINISTRACION O DIRECCION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45593 , F 173, S 8, H M 582661, I/A 51 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-28
- AVDA DE BRUSELAS 35 (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45593 , F 173, S 8, H M 582661, I/A 50 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45593 , F 170, S 8, H M 582661, I/A 49 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28