OFSA DEVOLUCIONES SA
Municipio Guadalajara
Provincia Guadalajara
Razón Social OFSA DEVOLUCIONES SA
CIF A19231935
Actividad Manipulación de mercancías
Fecha de Constitución 13/12/2005
Página Web www.ofsa.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Alejandro Mingo Pedroche
ORGANIGRAMA DE OFSA DEVOLUCIONES SA
VINCULACIONES DE OFSA DEVOLUCIONES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OFSA DEVOLUCIONES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alejandro Mingo Pedroche | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/01/2024 | |
Alejandro Mingo Pedroche | Presidente | 09/01/2024 | |
Alejandro Mingo Pedroche | Consejero | 09/01/2024 | |
Alberto Serrano Deville Bellechasse | Apoderado Solidario | 26/09/2023 | |
Cortes Robledo Jose Luis | Apoderado Solidario | 16/05/2022 | |
Lopez Anton Manuel Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/11/2021 | |
Garcia Lopez Alba | Apoderado Solidario | 09/12/2020 | |
Hernan-carrillo Portoles Santiago | Apoderado Solidario | 28/10/2020 | |
Cosmen Fernandez Alvaro | Secretario No Consejero | 01/07/2020 | |
Lewin De Orozco Luz Lourdes | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/07/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OFSA DEVOLUCIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 116, S 8, H GU 5514, I/A 39 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-19
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 116, S 8, H GU 5514, I/A 39 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-19
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 116, S 8, H GU 5514, I/A 39 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-19
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 116, S 8, H GU 5514, I/A 38 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-19
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 116, S 8, H GU 5514, I/A 38 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-19
- Conforme al artículo 62.3 del Reglamento General de Recaudación se hace constar que se ha dictado con fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno por la Dependencia de Recaudación acuerdo =DECLARANDO FALLIDO= la entidad de esta hoja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 114, S 8, H GU 5514, I/A 36 n (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-19
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 114, S 8, H GU 5514, I/A 36 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-19
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 113, S 8, H GU 5514, I/A 35 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-19
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 113, S 8, H GU 5514, I/A 35 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-19
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 113, S 8, H GU 5514, I/A 34 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-19