JIM BARK SA
Dirección social Calle Castillo de Olite, 3
Código Postal 46910
Municipio Alfafar
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social JIM BARK SA
CIF A46261517
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Teléfono 96 375 10 11
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Sanchez Martinez Julian
ORGANIGRAMA DE JIM BARK SA
VINCULACIONES DE JIM BARK SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JIM BARK SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gimenez Garcia Visitacion | Secretario | 05/10/2022 | |
Gimenez Garcia Visitacion | Consejero Delegado | 05/10/2022 | |
Gimenez Garcia Visitacion | Consejero | 05/10/2022 | |
Sanchez Gimenez Marina | Consejero | 05/10/2022 | |
Sanchez Martinez Julian | Presidente | 05/10/2022 | |
Sanchez Martinez Julian | Consejero | 05/10/2022 | |
Sanchez Martinez Julian | Apoderado | 17/06/2021 | |
Talavan Salguero Juan Jose | Apoderado | 24/09/2019 |
ACTOS BORME DE JIM BARK SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4102, L 1414, F 44, S 8, H V 19100, I/A 19 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4102, L 1414, F 44, S 8, H V 19100, I/A 19 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4102, L 1414, F 43, S 8, H V 19100, I/A 18 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4102, L 1414, F 43, S 8, H V 19100, I/A 17 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-46
- Otras modificaciones estatutarias: El Consejo de Administración estará integrado por tres Consejeros como mínimo y doce como máximo. La duración del cargo de Consejero será de seis años. Para ser designado Consejero no se precisará ser accionista. El Consejo designará en su seno un Presidente y un Secretario. El Consejo celebrará se
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4102, L 1414, F 43, S 8, H V 19100, I/A 16 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4102, L 1414, F 42, S 8, H V 19100, I/A 15 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4102, L 1414, F 42, S 8, H V 19100, I/A 15 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-46
- C/ CASTILLO DE OLITE 3 (ALFAFAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4102, L 1414, F 42, S 8, H V 19100, I/A 14 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4102, L 1414, F 42, S 8, H V 19100, I/A 13 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-117-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4102, L 1414, F 42, S 8, H V 19100, I/A 13 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-117-46