GECOL SILICES SL - EXTINGUIDA
Municipio Fuentes de Andalucía
Provincia Sevilla
Razón Social GECOL SILICES SL
CIF B91531301
Capital Social 4170000.0 Euros
Actividad Extracción de gravas y arenas; extracción de arcilla y caolín
Fecha de Constitución 23/02/2006
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario SAO SERVICIOS GCL SL
VINCULACIONES DE GECOL SILICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GECOL SILICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernal Vicente Alejandro | Secretario | 13/06/2022 | 12/08/2024 |
Bernal Vicente Alejandro | Consejero | 13/06/2022 | 12/08/2024 |
Bernal Vicente Alejandro | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/07/2022 | 12/08/2024 |
Bindschedler Pierre Etienne | Apoderado Mancomunado | 12/08/2024 | |
Bindschedler Pierre Etienne | Presidente | 13/06/2022 | 12/08/2024 |
Bindschedler Pierre Etienne | Consejero Delegado | 13/06/2022 | 12/08/2024 |
Bindschedler Pierre Etienne | Consejero | 13/06/2022 | 12/08/2024 |
Bindschedler Pierre Etienne | Apoderado Mancomunado | 11/07/2022 | 12/08/2024 |
Osca Ribera Juan Bautista | Apoderado | 05/12/2019 | 12/08/2024 |
Pereira Da Cunha Oliveira Paulo Virginio | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/07/2022 | 12/08/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GECOL SILICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 67296, I/A 13 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 67296, I/A 13 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 67296, I/A 13 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 67296, I/A 13 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-41
- EXTENDIDA la correspondiente nota marginal de INEXISTENCIA DE OBSTACULOS REGISTRALES a que se refiere el Artículo 231.2 del Reglamento del Registro Mercantil con efecto de cierre provisional de la hoja de la sociedad de referencia durante el plazo de seis meses, a contar desde esta fecha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4386 , F 204, S 8, H SE 67296, I/A 11 b (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4386 , F 204, S 8, H SE 67296, I/A 11 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4386 , F 202, S 8, H SE 67296, I/A 10 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-41
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4386 , F 202, S 8, H SE 67296, I/A 9 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4386 , F 202, S 8, H SE 67296, I/A 8 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-41
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4386 , F 201, S 8, H SE 67296, I/A 7 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-41