GECOL MORTEROS SUR SL - EXTINGUIDA
Razón Social GECOL MORTEROS SUR SL
CIF B91089326
Capital Social 1078220.0 Euros
Nombres Anteriores
- GECOL SEVILLA SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario HOLDING SOPREMA SA
Auditor FORVIS MAZARS AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE GECOL MORTEROS SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GECOL MORTEROS SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernal Vicente Alejandro | Consejero | 13/06/2022 | 12/08/2024 |
Bernal Vicente Alejandro | Secretario | 13/06/2022 | 12/08/2024 |
Bernal Vicente Alejandro | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/07/2022 | 12/08/2024 |
Bindschedler Pierre Etienne | Apoderado Mancomunado | 12/08/2024 | |
Bindschedler Pierre Etienne | Presidente | 13/06/2022 | 12/08/2024 |
Bindschedler Pierre Etienne | Consejero | 13/06/2022 | 12/08/2024 |
Bindschedler Pierre Etienne | Consejero Delegado | 13/06/2022 | 12/08/2024 |
Bindschedler Pierre Etienne | Apoderado Mancomunado | 11/07/2022 | 12/08/2024 |
FORVIS MAZARS AUDITORES SLP | Auditor | 30/12/2022 | 12/08/2024 |
HOLDING SOPREMA SA | Socio Unico | 13/06/2022 | 12/08/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GECOL MORTEROS SUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 42460, I/A 14 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 42460, I/A 14 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 42460, I/A 14 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 42460, I/A 14 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-41
- EXTENDIDA la correspondiente nota marginal de INEXISTENCIA DE OBSTACULOS REGISTRALES a que se refiere el Artículo 231.2 del Reglamento del Registro Mercantil con efecto de cierre provisional de la hoja de la sociedad de referencia durante el plazo de seis meses, a contar desde esta fecha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7242 , F 91, S 8, H SE 42460, I/A 12 b (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3165 , F 212, S 8, H SE 42460, I/A 12 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-7-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3165 , F 212, S 8, H SE 42460, I/A 11 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3165 , F 210, S 8, H SE 42460, I/A 10 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-41
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3165 , F 210, S 8, H SE 42460, I/A 9 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3165 , F 210, S 8, H SE 42460, I/A 8 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-41