DERMAC SA
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social DERMAC SA
CIF A20153540
Capital Social 60040.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Teléfono 94 328 23 05
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Gracia Maza Carlos Jesus
ORGANIGRAMA DE DERMAC SA
VINCULACIONES DE DERMAC SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DERMAC SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castro Hernandez Matilde | Consejero | 12/11/2019 | |
Cousillas Perez Fernando | Consejero | 12/11/2019 | |
Gracia Maza Carlos Jesus | Presidente | 12/11/2019 | |
Gracia Maza Carlos Jesus | Consejero | 12/11/2019 | |
Leceta Gracia Ana Maria | Consejero | 12/11/2019 | |
Parra Calderon Nicolas | Secretario | 12/11/2019 | |
Parra Calderon Nicolas | Consejero | 12/11/2019 | |
Gracia Maza Carlos Jesus | Apoderado Solidario | 23/03/2016 | |
Parra Calderon Nicolas | Apoderado Solidario | 23/03/2016 | |
Cousillas Jimenez Jose Fernando | Consejero | 12/03/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DERMAC SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213 , F 113, S 8, H SS 4255, I/A 15 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-20
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213 , F 113, S 8, H SS 4255, I/A 15 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-20
Capital Anterior: | 37.983,96 | Euros |
Aumento de capital: | 22.056,04 | Euros |
Capital Actual: | 60.040,00 | Euros |
Porcentaje: | 58,07 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213 , F 113, S 8, H SS 4255, I/A 14 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-20
Capital Anterior: | 60.101,21 | Euros |
Disminución de capital | 22.117,25 | Euros |
Capital Actual: | 37.983,96 | Euros |
Porcentaje: | 36,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213 , F 113, S 8, H SS 4255, I/A 14 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-20
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213 , F 112, S 8, H SS 4255, I/A 13 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-20
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213 , F 111, S 8, H SS 4255, I/A 12 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-20
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213 , F 111, S 8, H SS 4255, I/A 11 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-20
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213 , F 111, S 8, H SS 4255, I/A 11 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-20
- Otras modificaciones estatutarias: cargo de consejeros es de SEIS AÑOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213 , F 111, S 8, H SS 4255, I/A 10 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-20
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213 , F 111, S 8, H SS 4255, I/A 10 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-20