BRUTAL MEDIA SL
Dirección social Cl Berlines, 46
Código Postal 08022
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BRUTAL MEDIA SL
CIF B64841406
Capital Social 103000.0 Euros
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Fecha de Constitución 26/03/2008
Teléfono 93 420 02 06
Página Web www.brutalmedia.tv
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Jacob Daniel De Boer
ORGANIGRAMA DE BRUTAL MEDIA SL
VINCULACIONES DE BRUTAL MEDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BRUTAL MEDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Masllorens Escubos Raimundo | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/12/2024 | |
Sanchez Lago Nelida | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/12/2024 | |
Helen Fox Gladwell | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/04/2024 | |
Jacod Daniel De Boer | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/04/2024 | |
Masllorens Escubos Raimundo | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/04/2024 | |
Sanchez Lago Nelida | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/04/2024 | |
Helen Fox Gladwell | Secretario | 24/04/2024 | |
Helen Fox Gladwell | Consejero | 24/04/2024 | |
Jacob Daniel De Boer | Presidente | 24/04/2024 | |
Jacob Daniel De Boer | Consejero | 24/04/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BRUTAL MEDIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 368846, I/A 16 (30/12/2024)
CVE: BORME-A-2025-3-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46379 , F 9, S 8, H B 368846, I/A 15 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46379 , F 9, S 8, H B 368846, I/A 15 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO. NUEVO SOCIO UNICO: BBC STUDIOS DISTRIBUTION LIMITED
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40719 , F 191, S 8, H B 368846, I/A 14 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 4.- FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DE ABRIL Y FINALIZANDO EL 31 DE MARZO DE CADA AÑO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40719 , F 191, S 8, H B 368846, I/A 14 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-08
Presidente
Secretario
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40719 , F 191, S 8, H B 368846, I/A 14 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40719 , F 191, S 8, H B 368846, I/A 14 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-08
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 103.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40719 , F 191, S 8, H B 368846, I/A 13 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40719 , F 191, S 8, H B 368846, I/A 12 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-08
- Sociedades beneficiarias de la escisión: STUDIO 87 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40443 , F 154, S 8, H B 368846, I/A 11 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-08