ARENADIRC SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 71
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARENADIRC SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 07/10/2013
Página Web convocatoria junta en la pagina web de la sociedad gestora
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ARENADIRC SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARENADIRC SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Almagro Bernal Josep Antoni | Consejero | 07/10/2013 | 15/12/2022 |
BANCO DE SABADELL SA | Entidad Depositaria | 07/10/2013 | 15/12/2022 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 26/03/2021 | 15/12/2022 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Secretario No Consejero | 15/02/2021 | 15/12/2022 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Apoderado | 19/04/2022 | 15/12/2022 |
Ferrer Merigo Montserrat | Consejero | 07/10/2013 | 15/12/2022 |
Ferrer Merigo Montserrat | Consejero Delegado | 07/10/2013 | 15/12/2022 |
Ferrer Merigo Montserrat | Presidente | 07/10/2013 | 15/12/2022 |
Ferrer Merigo Montserrat | Consejero Delegado | 23/10/2019 | 15/12/2022 |
Ferrer Merigo Montserrat | Liquidador | 15/12/2022 | 15/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARENADIRC SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36686 , F 211, S 8, H M 657723, I/A 9 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36686 , F 211, S 8, H M 657723, I/A 9 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
- DADA DE BAJA LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE LA CNMV POR RESOLUCION DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2022, DONDE ESTA INSCRITA CON EL NUMERO 3879, Y REVOCADA LA DESIGNACION DE IBERCLEAR COMO ENTIDAD ENCARGADA DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS ACCIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36686 , F 211, S 8, H M 657723, I/A 9 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36686 , F 211, S 8, H M 657723, I/A 9 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36686 , F 211, S 8, H M 657723, I/A 9 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36686 , F 211, S 8, H M 657723, I/A 9 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36686 , F 211, S 8, H M 657723, I/A 8 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-28
- Revocado el nombramiento como auditor de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL para el ejercicio 2021
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36686 , F 210, S 8, H M 657723, I/A 7 (09/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36686 , F 210, S 8, H M 657723, I/A 7 (09/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 1º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36686 , F 210, S 8, H M 657723, I/A 6 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-28